Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Home
Search
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Print
Search
•
Advanced Search
•
Search Families
•
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Alice Pierce
1600 - 1647 (47 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Alice Pierce
[1]
b. 1600 d. 1647
Thomas Bennett
b. 1580 d. 1640
2
Mary Bennett
[1.1]
b. 1627 d. 1700
Richard Jackson
b. 1597 d. 1666
3
Sarah Jackson
[1.1.1]
b. 1642
Arthur Smith
b. 1638 d. 1696
4
Mary Smith
[1.1.1.1]
b. 1656 d. 1702
William Fly
b. 1658 d. 1679
5
Jeremiah Fly
[1.1.1.1.1]
b. 1679 d. 1735
Mary Tyler
b. 1685 d. 1736
6
John Fly
[1.1.1.1.1.1]
b. 1707 d. 1795
Dorothy Slover
b. 1707 d. 1747
7
William Fly
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 1727 d. 1795
Mary Nicholas
b. 1727 d. 1795
8
Elisha Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1748 d. 1795
Margaret Allman
b. 11 Jan 1755 d. 1802
9
Elisha Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1767 d. 1840
+
Elizabeth Reed
b. 1772 d. Bef 1847
9
Jeremiah Duncan Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1772 d. 17 Nov 1846
Zilpha Pipkin
b. 1 Jan 1777 d. Dec 1843
10
William Asher Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 17 Nov 1799 d. Sep 1849
Nicea Sooter
b. 1803 d. 1875
11
Nancy Matilda Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 1826 d. 4 Jan 1850
James Roden
b. 9 Jan 1819 d. 5 May 1899
12
Levi Roden
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 1842
12
William Edward Roden
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 1844
12
John Wesley Roden
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3]
b. 12 Apr 1846 [
=>
]
12
Greenberry B Roden
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.4]
b. 15 Mar 1848
12
Elisha Roden
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.5]
b. 4 Jan 1850
12
Elijah Roden
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.6]
b. 4 Jan 1850
11
Elisha Brown Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 16 May 1828 d. 25 Apr 1863
Rebecca Ann Marbut
b. 28 Dec 1828 d. 2 Mar 1902
12
William M Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1]
b. 5 Feb 1851 d. 26 Aug 1853
12
Sarah A Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.2]
b. 16 Oct 1852 d. 26 Aug 1853
12
Dolly A Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.3]
b. 19 Jun 1854 d. 18 Jun 1930 [
=>
]
12
Samantha Caroline Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.4]
b. 19 Oct 1856 d. 10 Oct 1948 [
=>
]
12
Mary Rowena Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.5]
b. 1 Dec 1858 d. 14 Jun 1938
12
Carroll Adkerson Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.6]
b. 20 Jan 1862 d. 20 Dec 1948 [
=>
]
11
Sarah Melvina Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 25 Jun 1833 d. 13 Feb 1902
Lewis Smith
b. 26 Dec 1830 d. 20 Oct 1911
12
Nicea Emeline Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1]
b. 1856
12
Charles Ivy Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2]
b. 19 Feb 1859
12
Calvin Lafayette Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.3]
b. 19 Mar 1861
12
Asher Coleman Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.4]
b. 14 Dec 1863 d. 8 Jan 1942
12
Lewis Albion Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.5]
b. 22 May 1866 d. 1 Dec 1928
12
Melvina Cyrina Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.6]
b. 1868
12
Ida D Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.7]
b. 1870
12
Letha Jane Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.8]
b. 18 Feb 1872 d. 1950 [
=>
]
11
Permelia Rowena Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 4 Jan 1837 d. 10 Mar 1915
George Washington Marbut
b. 12 Oct 1830 d. 3 Nov 1911
12
Elisha A Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.1]
b. Dec 1852
12
John Wesley Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.2]
b. 21 Dec 1855 d. 1942
12
George D Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.3]
b. 15 May 1856 d. 1934 [
=>
]
12
Amanda Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.4]
b. 1859
12
Melvina Elizabeth Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.5]
b. 14 Oct 1862 d. 12 Aug 1873
12
Martha Rowena Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.6]
b. 1865
12
Nettie B Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.7]
b. 1867
12
Meridith Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.8]
b. 1867
12
Miranda Jane Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.9]
b. 5 May 1869
12
Infant Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.10]
b. 1 Jan 1871 d. 1 Jan 1871
12
Ira Madison Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.11]
b. 8 Feb 1873 d. 1939
12
Talitha Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.12]
b. 1875
12
Edmond Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.13]
b. 1877
12
Columbus L Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.14]
b. 9 Oct 1879
12
Herschel Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.15]
b. 1881
12
Wilmer Marbut
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.16]
b. 1883
11
Martha Emeline Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 14 Dec 1838 d. Oct 1926
Francis Marion Henderson
b. 11 Jul 1831 d. 30 Jul 1905
12
Amanda Paralee Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.1]
b. 11 Mar 1856
12
James Tillman Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.2]
b. 12 Oct 1859 d. 19 Mar 1923
12
William Riley Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.3]
b. 28 Aug 1861
12
Francis Pinkney Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.4]
b. 12 Jul 1864
12
Deniza Elzona Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.5]
b. 14 Dec 1866
12
Nicea Louisa Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.6]
b. 12 Apr 1869
12
Pleasant Reuben Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.7]
b. 30 Mar 1870
12
Hosea Lafayette Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.8]
b. 25 Jul 1873 d. Bef 1920 [
=>
]
12
Joseph Greenberry Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.9]
b. 6 Oct 1875 d. 16 Mar 1965
12
Mary Permelia Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.10]
b. 8 May 1880 d. 12 May 1982
12
Wesley S Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.11]
b. 29 Aug 1880
12
Calvin Emory Henderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.12]
b. 4 Apr 1884
11
Asher Pipkin Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6]
b. 5 Jun 1841 d. 15 Nov 1901
Sarah Matilda Patrick (Johns)
b. 23 Sep 1842 d. 30 Apr 1914
12
William Jefferson Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.1]
b. 16 Dec 1861 d. 4 Mar 1919 [
=>
]
12
Levi Elbert Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.2]
b. 3 Jun 1864 [
=>
]
12
Marinda Mae Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.3]
b. 1867 [
=>
]
12
Horace Webster Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.4]
b. 24 Nov 1868 d. 17 Dec 1951 [
=>
]
12
Malinda Caroline Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.5]
b. 1870
12
Martha Rowena Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.6]
b. 3 Aug 1873 d. 19 Jun 1947 [
=>
]
12
Elisha Matthew Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.7]
b. 25 Feb 1876 d. 20 Nov 1917 [
=>
]
12
Arminda Emmaline Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.8]
b. 1879
12
Mary Isabel Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.9]
b. 23 Sep 1881 d. 5 Jun 1947 [
=>
]
12
Sarah Levina Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.10]
b. Feb 1885
11
Stacey Elenor Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7]
b. 3 Nov 1844 d. 14 Dec 1941
William Thomas Moudy
12
Moses Moudy
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.1]
b. 19 Apr 1872 d. 29 Dec 1893
11
Lavina Penelope Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8]
b. 16 Oct 1846 d. 20 Jan 1903
+
Henry Jefferson Smith
b. 18 Jan 1838 d. 12 Sep 1930
11
William Boone Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.9]
b. 1848 d. 1866
11
Infant Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.10]
b. 23 Apr 1848 d. 23 Apr 1848
11
Infant Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.11]
b. 3 Apr 1849 d. 3 Apr 1849
11
Infant Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.12]
b. 8 Feb 1857 d. 8 Feb 1857
11
Nicholas M Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.13]
b. 18 Oct 1863 d. 22 Sep 1864
10
Annah Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 15 Jul 1802 d. 1863
William R Sooter
b. 13 Mar 1802 d. 1865
11
Maria Louisa Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 25 Jun 1825 d. 25 Dec 1904
+
John K Howerton
+
Samuel P Strother
11
Albert J Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2]
b. 2 Mar 1827 d. 25 Dec 1900
Edna Kessinger
b. 1827
12
James M Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.1]
b. 1850
12
Joseph Marion Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.2]
b. 1 May 1852 d. 3 Feb 1940
12
Elizabeth Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.3]
b. 1854
12
Thomas Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.4]
b. 1856
12
Martha Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.5]
b. 1859
12
John F Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.6]
b. 1861
12
Tilman Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.7]
b. 1863
12
Milton Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.8]
b. 1865
12
Sarah Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.9]
b. 1868
11
James Madison Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3]
b. 18 Nov 1830
Margaret Sturdy
b. 1833
12
Elizabeth Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.1]
b. 1863
12
James Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.2]
b. 1876
11
William E W Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4]
b. 15 Oct 1832
11
Edward Marion Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5]
b. 25 Nov 1834
+
Martha Elizabeth Matlock
11
Martha Ann Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6]
b. 31 Mar 1837
11
Benjamin Franklin Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7]
b. 8 Jan 1839 d. 1866
Margaret T Smith
b. 1839
12
General P Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7.1]
b. 6 Jan 1862 d. 10 Jun 1939 [
=>
]
12
Tabitha Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7.2]
b. 1863
12
Benjamin Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7.3]
b. 1864
11
Elizabeth C Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8]
b. 8 Jan 1839
11
Monroe Jackson Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9]
b. 12 May 1844
10
Mary Penelope Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 1803 d. Abt 1861
Dr. Jonathan Bullock
b. 1793 d. 15 Feb 1861
11
Martha Rowena Bullock
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 19 Dec 1822
+
Thomas Pogue
11
Athen T Bullock
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.2]
b. 1830
+
Nancy E Frazier
11
Samuel D Bullock
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3]
b. 1832
+
Margaret Foster
11
Nevel C Bullock
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4]
b. 1834
10
Asher Pipkin Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 9 Aug 1804 d. 22 Dec 1868
Marilla Elizabeth Cantrell
b. 18 Dec 1804 d. 25 Mar 1860
11
Eliza Ann Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1]
b. 2 Apr 1824 d. 1 Jan 1863
James Abraham Swindle
b. 30 Oct 1822 d. 2 Aug 1900
12
John Swindle
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.1]
b. 31 Oct 1854 d. 18 Apr 1930 [
=>
]
12
Martha Jane Swindle
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.2]
b. 1856 d. 1941
12
Lafayette Swindle
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.3]
b. 1858
12
George Swindle
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.4]
b. 1859
12
Eliza Swindle
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.5]
b. 1864
12
Abraham "Abe" Swindle
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.6]
b. 1867
11
Albert Latimer Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2]
b. 16 Apr 1828 d. 2 May 1896
Sophronia Virginia Ferguson
b. 8 Jun 1831 d. 8 Nov 1914
12
Melissa Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.1]
b. 20 Jan 1851 d. Abt 1885 [
=>
]
12
John Bryan Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.2]
b. 29 Jan 1852 d. 3 Jan 1882 [
=>
]
12
William Bertrand Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.3]
b. 8 Dec 1853 d. 26 May 1937 [
=>
]
12
Asher Pipkin Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.4]
b. 18 Mar 1855 d. 23 Jul 1935 [
=>
]
12
Thurston D Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.5]
b. 17 Jan 1857 d. 13 Jun 1857
12
Feriaba (Feriba) Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.6]
b. 11 Apr 1858 d. 10 Nov 1932 [
=>
]
12
Mary Alice Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.7]
b. 24 Dec 1859 d. 18 Dec 1930
12
Dallas B Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.8]
b. 30 Sep 1861 d. 2 May 1883
12
Palestine Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.9]
b. 15 Sep 1867 d. 22 Nov 1868
12
Buena Vista Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.10]
b. 16 Dec 1868 d. 19 Nov 1917 [
=>
]
12
Florence Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.11]
b. 3 Mar 1870 d. 18 Jan 1951 [
=>
]
12
Laura Belle Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.12]
b. 20 Mar 1872 d. 18 Dec 1950 [
=>
]
12
Albert Elmore Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.13]
b. 1 Jun 1874 d. 3 Jul 1962 [
=>
]
12
Elbert Latimer Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.14]
b. 1 Jun 1874 d. 7 Jun 1957 [
=>
]
11
Sarah Jane Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3]
b. 17 Mar 1829
Wiley Surgnier
b. 1826
12
Marella Surgnier
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.1]
b. 1850
12
Richard Surgnier
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.2]
b. 1854
12
Albert Surgnier
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.3]
b. 1855
12
George Surgnier
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.4]
b. 1859
12
Wiley Surgnier
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.5]
b. 1862
12
Gramblin Surgnier
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.6]
b. 1869
11
Emily Catherine Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4]
b. 5 May 1830 d. 5 Apr 1912
Rufus Howerton
b. 1 Jun 1824 d. 6 Aug 1896
12
Samantha Jane Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.1]
b. 26 Jul 1851 d. 19 Apr 1941 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.2]
b. 16 Aug 1853 d. 16 Mar 1930 [
=>
]
12
George Jackson Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.3]
b. 5 Nov 1855
12
John Alexander Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.4]
b. 17 Mar 1857 d. 11 Mar 1926
12
Christopher Columbus Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.5]
b. 15 Jun 1857
12
William Monroe Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.6]
b. 1 Feb 1861 d. 29 Aug 1950 [
=>
]
12
Columbia Angelina Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.7]
b. 20 Jan 1863 [
=>
]
12
Charles Tillman Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.8]
b. 21 Nov 1864 d. 26 Jun 1928
12
Silas T Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.9]
b. 1866
12
Carlis Charter Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.10]
b. 13 Mar 1867 d. 28 Apr 1929
12
Calvin Leonados Howerton
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.11]
b. 28 Jan 1869 d. 7 Apr 1926
11
Jeremiah W N Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5]
b. 12 Nov 1831 d. 9 Apr 1864
Lavina Clark
b. 14 Oct 1837 d. 18 Jul 1921
12
Lorenzo Dow Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.1]
b. 22 Sep 1856 d. 11 Feb 1926 [
=>
]
12
Christopher Columbus Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.2]
b. 11 Jan 1858 d. 14 Feb 1859
12
Milton Asher Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.3]
b. 19 Jan 1859 d. 21 Mar 1944 [
=>
]
12
Calvin Winfield Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.4]
b. 8 Nov 1861 d. 23 Sep 1920 [
=>
]
12
William Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.5]
b. 15 Mar 1863 d. 10 Sep 1865
11
Elizabeth Penelope Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.6]
b. 4 Apr 1833 d. 18 Oct 1926
James Madison Dabbs
b. 9 Feb 1834 d. 19 Jun 1896
12
Martha M Dabbs
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.6.1]
b. 16 Dec 1855
12
Dalton Fletcher Dabbs
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.6.2]
b. 1857
12
John Calvin Dabbs
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.6.3]
b. 1860
12
Lucinda Jane Dabbs
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.6.4]
b. 13 Oct 1861
12
Elizabeth "Lizzy" Dabbs
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.6.5]
b. 14 Jan 1871 d. 20 Jun 1911
11
Tillmon Gregory Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.7]
b. 13 Feb 1836 d. 16 Aug 1913
+
Tempa Elenor Carson
b. Abt 1838
Margaret Alexander
b. 13 Aug 1843 d. 25 May 1928
12
Francis Lavina Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.7.1]
b. 18 Sep 1868 d. 15 May 1966 [
=>
]
12
Charles Wallace Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.7.2]
b. 3 Dec 1869 d. 22 Apr 1948 [
=>
]
12
Rilla Margaret Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.7.3]
b. 1872 d. 1953 [
=>
]
12
Olive Mae Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.7.4]
b. 1876 d. 1959 [
=>
]
11
Jonathan Dalton Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.8]
b. 4 Mar 1838 d. 29 Apr 1864
Mary Ann Patton
b. 9 Jan 1841 d. 16 Dec 1908
12
Calvin Harris Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.8.1]
b. 20 Oct 1859 d. 5 Feb 1934 [
=>
]
12
Florida Isabell Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.8.2]
b. 25 Apr 1861 d. 1 Mar 1946
12
Andrew Jackson Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.8.3]
b. 26 Mar 1862 d. 12 Nov 1921 [
=>
]
11
Rachel Rowena Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9]
b. 8 Jan 1840
George Hill
b. 1837
12
Sterling W Hill
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9.1]
b. 1859
11
Margaret Elvira Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10]
b. 20 Mar 1841 d. 23 Feb 1920
John M Pitcock
b. 15 Aug 1837 d. 29 May 1905
12
Athur Pitcock
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.1]
b. 1866
12
Rilla E Pitcock
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.2]
b. 1869
12
Francis E Pitcock
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.3]
b. 1874
12
Eliza Ellen Pitcock
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.4]
b. 1876
+
James Fletcher Patton
b. 22 Sep 1839 d. 29 Oct 1873
11
Thomas Hart Benton Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.11]
b. 11 Jul 1842 d. Sep 1844
11
John Wesley Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.12]
b. 7 Mar 1844 d. 20 Jan 1924
Charioty Clark
b. 1 Aug 1844 d. 26 Apr 1931
12
Fountain E Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.12.1]
b. 8 Mar 1865 d. 21 Mar 1945 [
=>
]
12
Miranda Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.12.2]
b. 3 Jan 1867 d. 23 Nov 1956 [
=>
]
12
Gertrude Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.12.3]
b. 5 Mar 1872 d. 23 Feb 1952 [
=>
]
12
Roxie Ellen Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.12.4]
b. 16 May 1874 d. 24 Nov 1963
12
Alice (Allie) Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.12.5]
b. 31 Aug 1880
11
Nancy Lavina Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.13]
b. 1 Apr 1846 d. 13 Sep 1857
11
Artela Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.14]
b. 22 Nov 1849 d. 11 Jan 1913
John Hugh Clark
b. 7 Jan 1848 d. 11 Dec 1920
12
Louisa Belle Clark
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.14.1]
b. 13 Oct 1867 d. 8 Feb 1945
12
John Wesley Clark
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.14.2]
b. 7 Jun 1875 [
=>
]
Minerva Ann Doty
b. 7 Dec 1841 d. 12 Jun 1903
11
Florida Gazette Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.15]
b. 30 Oct 1863 d. 3 Apr 1932
William Harmon Getchell
b. 30 Mar 1850 d. 27 Mar 1927
12
Alberta Fly Getchell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.15.1]
b. 23 Jun 1892 d. 16 May 1960 [
=>
]
12
Wiley Getchell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.15.2]
b. 1893
12
Wallace Getchell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.15.3]
b. 1893 d. 1893
12
Leroy Harman Getchell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.15.4]
b. 2 Dec 1896 d. 25 May 1975
12
Clay Getchell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.15.5]
b. 1898 d. 1898
12
William B Getchell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.15.6]
b. 12 Nov 1900 d. 24 Nov 1969
12
Claud Getchell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.15.7]
b. 1902 d. 1904
12
Harold W Getchell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.15.8]
b. Jan 1905 d. 14 Mar 1982
11
Wiley Sylvester Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.16]
b. 1 May 1865 d. 13 Jan 1964
+
Myrtle Getchell
Florence Elizabeth Brock
b. 14 Feb 1873
12
Vera Maxie Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.16.1]
b. 30 Oct 1896 d. Mar 1981
12
Wendal Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.16.2]
b. 1898
12
Nova Grace Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.16.3]
b. 10 Apr 1900
12
Asher Percy Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.16.4]
b. 25 Aug 1902 d. 26 Jun 1990
12
Virgil George Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.16.5]
b. 14 Sep 1906 d. 19 Jul 1997
12
Shelby Morris Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.16.6]
b. 2 Jul 1912 d. 12 Dec 1998
11
Caleb Monroe Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.17]
b. 19 Feb 1867 d. 4 Feb 1916
Molly Johnston
b. 1870
12
Jennie L Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.17.1]
b. Abt 1900
11
Oceanda Pipkin Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.18]
b. 23 May 1869 d. 2 Jul 1926
James Smith
b. 1864
12
Gertrude M (Gertie) Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.18.1]
b. Jan 1893
12
Ashley D Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.18.2]
b. Oct 1895
12
Derwood Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.18.3]
b. 10 Oct 1896
12
Bonnie Gladys Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.18.4]
b. Sep 1898
12
Living
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.18.5]
12
Living
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.18.6]
12
Living
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.18.7]
10
Margaret Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 1807 d. 1865
Greenberry Asbury Sooter
b. 1805 d. 6 May 1886
11
Milton C Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1]
b. 30 Nov 1826 d. 18 Feb 1875
Martha Matlock
b. 7 Jan 1826 d. 26 Jan 1872
12
Sarah Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1.1]
b. Jun 1850
12
Christopher Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1.2]
b. 7 Jun 1855 d. 3 Jun 1858
12
Lafayette Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1.3]
b. 15 Mar 1861 d. 24 Dec 1861
11
Elizabeth Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.2]
b. 1828
10
Jeremiah Nicholas Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 5 Oct 1807 d. 6 Jan 1873
Nancy C Oakley\Henry
b. 22 Nov 1805 d. 14 Feb 1885
11
Hon William Alexander Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1]
b. 7 Mar 1826 d. 26 Feb 1918
Angeline Burney Leeper
b. 12 Apr 1837 d. 16 Jun 1867
12
William Monroe Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.1]
b. 1 Jan 1854 d. 1 Feb 1937
Martha A Hale
b. 8 May 1841 d. 2 Jul 1921
12
Henry Wilson Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2]
b. 24 May 1876 d. 1 May 1956
Naomi Surgnier
b. 21 Aug 1829 d. 6 Oct 1861
12
Infant Son Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.3]
b. 23 Apr 1848 d. 23 Apr 1848
12
Infant Son Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.4]
b. 3 Apr 1849 d. 3 Apr 1849
12
Jasper Lafayette Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.5]
b. 22 Apr 1850 d. 15 Apr 1897 [
=>
]
12
Sydney Ann Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.6]
b. 20 Oct 1852 d. 28 Feb 1853
12
Mary Jane Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.7]
b. 1853
12
William Monroe Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.8]
b. 1 Jan 1854 d. 1 Feb 1937
12
Richard William Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.9]
b. 21 Jan 1856 d. 29 Jul 1881
12
Infant Son Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.10]
b. 8 Feb 1857 d. 8 Feb 1857
11
Baron Decalb Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.2]
b. 4 Nov 1834 d. 1 May 1917
Margaret Jane Woodward
b. 18 Jun 1835 d. 23 Dec 1906
12
William Nicholas Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.2.1]
b. 20 Mar 1859 d. 3 Dec 1939
12
Louisa Jane Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.2.2]
b. 4 Jun 1866 d. 14 Feb 1946
11
Dr Martin Van Buren Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.3]
b. 17 Mar 1838 d. 26 May 1863
11
Rev John Benton Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.4]
b. 16 Aug 1840 d. 28 Aug 1905
+
Susan Esther Woodward
b. 28 Apr 1840 d. 12 Dec 1909
10
Martha Patsy Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 1 Jan 1809 d. 20 Sep 1899
Rev. Edward Greenberry Sooter
b. 1812 d. 1849
11
Asher Fly Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.1]
b. 15 Jun 1833 d. 24 Jul 1898
+
Nancy Russell
11
William Leonard Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.2]
b. 7 Jul 1835 d. 9 Nov 1863
+
Margaret Russell
11
Martin Van Buren Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.3]
b. 24 Aug 1837 d. 9 Dec 1912
+
Sarah Margaret McCoy
b. 31 Dec 1835 d. 13 Apr 1895
11
Greenberry Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.4]
b. 13 Jun 1840 d. 17 Jan 1917
+
Mary Magdalene Stephens
b. 1845
11
Elisha Henry Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.5]
b. 22 Jan 1841 d. 1912
Nancy C Cordella
b. 1841 d. 1903
12
Sarah Elizabeth Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.5.1]
b. 1863
12
Edward Greenberry Sooter, Jr
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.5.2]
b. 1868
12
Andrew W Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.5.3]
b. 18 Nov 1869 d. Sep 1875
12
Greenberry Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.5.4]
b. 1869
12
Asher H Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.5.5]
b. 1874
12
Elisha D Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.5.6]
b. 1877
12
Preston M Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.5.7]
b. 27 Jan 1880 d. 24 Oct 1971
11
Eli Brown Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.6]
b. 30 Nov 1843
11
Andrew Sparlin Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.7]
b. 23 Oct 1845
11
Edward Perkins Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.8]
b. 15 Oct 1847
Elizabeth
b. 1849
12
Sarah F Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.8.1]
b. 1870
12
James N Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.8.2]
b. 1871
12
Laura L Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.8.3]
b. 1875
12
Martha R Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.8.4]
b. 1877
12
Elisha M Sooter
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.8.5]
b. 1879
10
Elisha Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 23 Jan 1811 d. 23 Apr 1877
Anne Kennedy
b. 12 Apr 1811 d. 27 Sep 1871
11
Martha Jane Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1]
b. 28 Feb 1831 d. 18 Dec 1917
John Whittington
b. 28 Feb 1832
12
Ann Whittington
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.1]
b. 1854
12
James Whittington
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.2]
b. 1856
12
Francis Whittington
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.3]
b. 1863
12
Mandy Whittington
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.4]
b. 1866
11
Frances M Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.2]
b. 28 Dec 1833 d. 8 Sep 1866
Willaby Etheridge
b. 22 Jan 1831 d. 1 Feb 1896
12
Matilda Ann Etheridge
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.2.1]
b. 23 Jul 1852 [
=>
]
12
M J Etheridge
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.2.2]
b. 19 May 1860 d. 20 Jul 1860
12
Margaret Roenne Etheridge
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.2.3]
b. 1 Jun 1861
12
James Martin Etheridge
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.2.4]
b. 30 Aug 1866
12
Jasper N Etheridge
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.2.5]
b. 1877
11
William Anderson Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.3]
b. 22 Jul 1835 d. 5 Jan 1864
+
Sarah Ann Moore
b. 1839 d. 22 Feb 1863
11
James Kennedy Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4]
b. 12 May 1838 d. 1905
Leona Jane Wiles
b. 1844 d. 1934
12
William Anderson Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.1]
b. 5 Aug 1867 d. 17 Dec 1895 [
=>
]
12
Artelia America Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.2]
b. 1870 d. 27 May 1943 [
=>
]
12
Mary Jane Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.3]
b. 1 Feb 1873 d. 13 Dec 1957
12
James Harvey Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.4]
b. 12 May 1875 d. 5 Mar 1956
12
Mamie Ann Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.5]
b. 7 Jan 1879 d. 19 Sep 1949
12
Laura Belle Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.6]
b. 29 Sep 1888 d. 30 Jul 1889
12
Clarence Monroe Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.7]
b. 12 Apr 1883 d. Oct 1959
11
Margaret R Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.5]
b. 9 Sep 1840
11
Mary Pyonnye Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.6]
b. 27 Oct 1842
+
John Young
b. 1841
11
Zilpha A Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.7]
b. 16 Dec 1845
11
Matilda Ann Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.8]
b. 19 Nov 1847
John William Wiles
b. 1845
12
Francis M Wiles
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.8.1]
b. 1861
11
Sarah Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.9]
b. 11 Aug 1852
11
Susan Elmira Fly
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.10]
b. 30 May 1855 d. 26 Jan 1879
+
Adelissa Lunsford
b. 20 Dec 1820 d. 15 Oct 1915
6
Rachel Fly
[1.1.1.1.1.2]
b. 1710
6
Charity Fly
[1.1.1.1.1.3]
b. 1712
6
Mary Fly
[1.1.1.1.1.4]
b. 1714